Liste der Countys in Ohio

Liste der Countys in Ohio

Der US-Bundesstaat Ohio ist in 88 Countys unterteilt. Sie werden im folgenden mit ihrem County Seat (Kreisstadt), dem Gründungsdatum und dem Namensgeber aufgeführt. Die Spalte „Ursprung“ gibt an, aus welchen anderen Countys ein Neues entstand.


County
FIPS Code
[1]
County Seat
[2]
Gegründet
[2][3]
Ursprung
[4]
Namensherkunft
[3][4][5]
Bevölkerung
[1][2]
Fläche
[2]
Karte
 
Adams County 001 West Union 10. Juli 1797 Hamilton County John Adams (1735–1826), President zur Zeit der Gründung des Countys 000000000027330.000000000027.330 000000000001512.00000000001.512 km² (000000000058391.000000000058.391 sq mi) State map highlighting Adams County
Allen County 003 Lima 1. März 1820 Shelby County John Allen (1771/1772–1813), Soldat im Britisch-Amerikanischen Krieg[6] 000000000108473.0000000000108.473 000000000001047.00000000001.047 km² (000000000040443.000000000040.443 sq mi) State map highlighting Allen County
Ashland County 005 Ashland 24. Februar 1846 Wayne, Richland, Huron, und Lorain Countys Ashland, Heimat von Henry Clay. 000000000052523.000000000052.523 000000000001099.00000000001.099 km² (000000000042437.000000000042.437 sq mi) State map highlighting Ashland County
Ashtabula County 007 Jefferson 7. Juni 1807 Trumbull und Geauga Countys Ashtabula River, das „Fisch-Fluss“ in Algonquianisch bedeutet[7] 000000000102728.0000000000102.728 000000000001819.00000000001.819 km² (000000000070244.000000000070.244 sq mi) State map highlighting Ashtabula County
Athens County 009 Athens 1. März 1805 Washington County Athen 000000000062223.000000000062.223 000000000001313.00000000001.313 km² (000000000050676.000000000050.676 sq mi) State map highlighting Athens County
Auglaize County 011 Wapakoneta 14. Februar 1848 Allen, Mercer, Darke, Hardin, Logan, Shelby, und Van Wert Countys Auglaize River, das bei den Shawnee „Fluss der gefallenen Bäume“ bedeutet 000000000046611.000000000046.611 000000000001039.00000000001.039 km² (000000000040125.000000000040.125 sq mi) State map highlighting Auglaize County
Belmont County 013 St. Clairsville 7. September 1801 Jefferson und Washington Countys Belle monte, französisch für „Schöner Berg“ 000000000070226.000000000070.226 000000000001392.00000000001.392 km² (000000000053735.000000000053.735 sq mi) State map highlighting Belmont County
Brown County 015 Georgetown 1. März 1818 Adams und Clermont Countys General Jacob Brown (1775–1828), Offizier im Britisch-Amerikanischen Krieg 000000000042285.000000000042.285 000000000001274.00000000001.274 km² (000000000049176.000000000049.176 sq mi) State map highlighting Brown County
Butler County 017 Hamilton 1. Mai 1803 Hamilton County General Richard Butler (1743–1791), getötet in der Schlacht von Wabash 000000000332807.0000000000332.807 000000000001210.00000000001.210 km² (000000000046727.000000000046.727 sq mi) State map highlighting Butler County
Carroll County 019 Carrollton 1. Januar 1833 Columbiana, Stark, Harrison, Jefferson, und Tuscarawas Countys Charles Carroll (1737–1832), letzter überlebender Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung 000000000028836.000000000028.836 000000000001022.00000000001.022 km² (000000000039467.000000000039.467 sq mi) State map highlighting Carroll County
Champaign County 021 Urbana 1. März 1805 Greene und Franklin Countys Französisch für „Ebene“ als Beschreibung des Gebiets 000000000038890.000000000038.890 000000000001110.00000000001.110 km² (000000000042856.000000000042.856 sq mi) State map highlighting Champaign County
Clark County 023 Springfield 1. März 1818 Champaign, Madison, und Greene Countys General George Rogers Clark (1752–1818), der die Shawnee-Indianer bei Springfield besiegte 000000000144742.0000000000144.742 000000000001036.00000000001.036 km² (000000000039986.000000000039.986 sq mi) State map highlighting Clark County
Clermont County 025 Batavia 6. Dezember 1800 Hamilton County Französisch für „freier Berg“ 000000000177977.0000000000177.977 000000000001171.00000000001.171 km² (000000000045199.000000000045.199 sq mi) State map highlighting Clermont County
Clinton County 027 Wilmington 1. März 1810 Highland und Warren Countys George Clinton (1739–1812), Vizepräsident zur Zeit der Countygründung 000000000040543.000000000040.543 000000000001064.00000000001.064 km² (000000000041088.000000000041.088 sq mi) State map highlighting Clinton County
Columbiana County 029 Lisbon 1. Mai 1803 Jefferson und Washington Countys Abgeleitet von den Namen Christoph Columbus und Anna 000000000112075.0000000000112.075 000000000001379.00000000001.379 km² (000000000053246.000000000053.246 sq mi) State map highlighting Columbiana County
Coshocton County 031 Coshocton 31. Januar 1810 Muskingum und Tuscarawas Countys „Vereinigung der Wasser“ in der Sprache der Delaware-Indianer 000000000036655.000000000036.655 000000000001461.00000000001.461 km² (000000000056407.000000000056.407 sq mi) State map highlighting Coshocton County
Crawford County 033 Bucyrus 1. April, 1820 Delaware County Offizier William Crawford (1732–1782) 000000000046966.000000000046.966 000000000001041.00000000001.041 km² (000000000040211.000000000040.211 sq mi) State map highlighting Crawford County
Cuyahoga County 035 Cleveland 7. Juni 1807 Geauga County Cuyahoga River, das „Krummer Fluss“ auf Irokesisch bedeutet[8] 000000001393978.00000000001.393.978 000000000001187.00000000001.187 km² (000000000045849.000000000045.849 sq mi) State map highlighting Cuyahoga County
Darke County 037 Greenville 3. Januar 1809 Miami County General William Darke (1736–1801), Offizier im Unabhängigkeitskrieg 000000000053309.000000000053.309 000000000001553.00000000001.553 km² (000000000059980.000000000059.980 sq mi) State map highlighting Darke County
Defiance County 039 Defiance 7. April 1845 Williams, Henry, und Paulding Countys Fort Defiance, von Anthony Wayne 1794 errichtet 000000000039500.000000000039.500 000000000001065.00000000001.065 km² (000000000041116.000000000041.116 sq mi) State map highlighting Defiance County
Delaware County 041 Delaware 1. April 1808 Franklin County Delaware-Indianer 000000000110106.0000000000110.106 000000000001146.00000000001.146 km² (000000000044241.000000000044.241 sq mi) State map highlighting Delaware County
Erie County 043 Sandusky March 15, 1838 Huron und Sandusky Countys Erie-Indianer 000000000079551.000000000079.551 000000000000660.0000000000660 km² (000000000025488.000000000025.488 sq mi) State map highlighting Erie County
Fairfield County 045 Lancaster 9. Dezember 1800 Ross und Washington Countys Benannt nach den „schönen Feldern“ 000000000122759.0000000000122.759 000000000001308.00000000001.308 km² (000000000050511.000000000050.511 sq mi) State map highlighting Fairfield County
Fayette County 047 Washington Court House 1. März 1810 Ross und Highland Countys Marquis de Lafayette, Französischer Offizier und Aristokrat 000000000028433.000000000028.433 000000000001053.00000000001.053 km² (000000000040658.000000000040.658 sq mi) State map highlighting Fayette County
Franklin County 049 Columbus 30. April 1803 Ross und Wayne Countys Benjamin Franklin (1706–1791) 000000001068978.00000000001.068.978 000000000001398.00000000001.398 km² (000000000053987.000000000053.987 sq mi) State map highlighting Franklin County
Fulton County 051 Wauseon 1. April 1850 Lucas, Henry, und Williams Countys Robert Fulton (1765 – 1815), Erfinder des Dampfschiffs 000000000042084.000000000042.084 000000000001054.00000000001.054 km² (000000000040678.000000000040.678 sq mi) State map highlighting Fulton County
Gallia County 053 Gallipolis 30. April 1803 Washington und Adams Countys Gallien 000000000031069.000000000031.069 000000000001214.00000000001.214 km² (000000000046878.000000000046.878 sq mi) State map highlighting Gallia County
Geauga County 055 Chardon 1. März 1806 Trumbull County Ein Wort der Indianer für Waschbär 000000000090895.000000000090.895 000000000001045.00000000001.045 km² (000000000040366.000000000040.366 sq mi) State map highlighting Geauga County
Greene County 057 Xenia 1. Mai 1803 Hamilton und Ross Countys General Nathanael Greene (1742–1786), Offizier im Unabhängigkeitskrieg 000000000147886.0000000000147.886 000000000001075.00000000001.075 km² (000000000041488.000000000041.488 sq mi) State map highlighting Greene County
Guernsey County 059 Cambridge 1. März 1810 Belmont und Muskingum Countys Guernsey 000000000040792.000000000040.792 000000000001352.00000000001.352 km² (000000000052190.000000000052.190 sq mi) State map highlighting Guernsey County
Hamilton County 061 Cincinnati 2. Januar 1790 Eines der ursprünglichen Countys Alexander Hamilton (1755/1757–1804) 000000000845303.0000000000845.303 000000000001055.00000000001.055 km² (000000000040736.000000000040.736 sq mi) State map highlighting Hamilton County
Hancock County 063 Findlay 1. April 1820 Logan County John Hancock (1737–1793) 000000000071295.000000000071.295 000000000001376.00000000001.376 km² (000000000053135.000000000053.135 sq mi) State map highlighting Hancock County
Hardin County 065 Kenton 1. April 1820 Logan County General John Hardin (1753–1792) 000000000031945.000000000031.945 000000000001218.00000000001.218 km² (000000000047029.000000000047.029 sq mi) State map highlighting Hardin County
Harrison County 067 Cadiz 1. Februar 1813 Jefferson und Tuscarawas Countys General William H. Harrison (1773–1841) 000000000015856.000000000015.856 000000000001045.00000000001.045 km² (000000000040353.000000000040.353 sq mi) State map highlighting Harrison County
Henry County 069 Napoleon 1. April 1820 Shelby County Patrick Henry (1736–1799) 000000000029210.000000000029.210 000000000001079.00000000001.079 km² (000000000041650.000000000041.650 sq mi) State map highlighting Henry County
Highland County 071 Hillsboro 1. Mai 1805 Ross, Adams, und Clermont Countys Beschreibung der Landschaft 000000000040875.000000000040.875 000000000001433.00000000001.433 km² (000000000055328.000000000055.328 sq mi) State map highlighting Highland County
Hocking County 073 Logan 1. März 1818 Athens, Ross, und Fairfield Countys Eventuell vom Wort der Delaware-Indianer „Hoch-Hoch-ing“, das „Flasche“ bedeutet 000000000028241.000000000028.241 000000000001095.00000000001.095 km² (000000000042275.000000000042.275 sq mi) State map highlighting Hocking County
Holmes County 075 Millersburg 20. Januar 1824 Coshocton, Wayne, und Tuscarawas Countys Major Andrew Holmes († 1814) 000000000038943.000000000038.943 000000000001096.00000000001.096 km² (000000000042299.000000000042.299 sq mi) State map highlighting Holmes County
Huron County 077 Norwalk 7. März 1809 Portage und Cuyahoga Countys Huron-Indianer 000000000059847.000000000059.847 000000000001276.00000000001.276 km² (000000000049269.000000000049.269 sq mi) State map highlighting Huron County
Jackson County 079 Jackson 1. März 1816 Scioto, Gallia, Athens, und Ross Countys General Andrew Jackson (1767–1845) 000000000032641.000000000032.641 000000000001089.00000000001.089 km² (000000000042028.000000000042.028 sq mi) State map highlighting Jackson County
Jefferson County 081 Steubenville 29. Juli 1797 Washington County Thomas Jefferson (1743–1826) 000000000073894.000000000073.894 000000000001061.00000000001.061 km² (000000000040961.000000000040.961 sq mi) State map highlighting Jefferson County
Knox County 083 Mount Vernon 1. März 1808 Fairfield County General Henry Knox 000000000054500.000000000054.500 000000000001365.00000000001.365 km² (000000000052712.000000000052.712 sq mi) State map highlighting Knox County
Lake County 085 Painesville 6. März 1840 Geauga und Cuyahoga Countys An den Ufern des Eriesees 000000000227511.0000000000227.511 000000000000591.0000000000591 km² (000000000022821.000000000022.821 sq mi) State map highlighting Lake County
Lawrence County 087 Ironton 21. Dezember 1815 Gallia und Scioto Countys Captain James Lawrence (1781–1813) 000000000062319.000000000062.319 000000000001178.00000000001.178 km² (000000000045496.000000000045.496 sq mi) State map highlighting Lawrence County
Licking County 089 Newark 1. März 1808 Fairfield County Nach den Salzlecken im County benannt 000000000145491.0000000000145.491 000000000001778.00000000001.778 km² (000000000068650.000000000068.650 sq mi) State map highlighting Licking County
Logan County 091 Bellefontaine 1. März 1818 Champaign County General Benjamin Logan (~1742–1802) 000000000046005.000000000046.005 000000000001187.00000000001.187 km² (000000000045844.000000000045.844 sq mi) State map highlighting Logan County
Lorain County 093 Elyria 26. Dezember 1822 Huron, Cuyahoga, und Medina Countys Nach Lorraine in Frankreich 000000000284664.0000000000284.664 000000000001276.00000000001.276 km² (000000000049250.000000000049.250 sq mi) State map highlighting Lorain County
Lucas County 095 Toledo 20. Juni 1835 Wood, Sandusky, und Huron Countys Robert Lucas (1781–1853), Gouverneur von Ohio 000000000455054.0000000000455.054 000000000000882.0000000000882 km² (000000000034046.000000000034.046 sq mi) State map highlighting Lucas County
Madison County 097 London 1. März 1810 Franklin County President James Madison (1751–1836) 000000000040213.000000000040.213 000000000001205.00000000001.205 km² (000000000046544.000000000046.544 sq mi) State map highlighting Madison County
Mahoning County 099 Youngstown 1. März 1846 Columbiana und Trumbull Countys Mahoning River 000000000257555.0000000000257.555 000000000001075.00000000001.075 km² (000000000041525.000000000041.525 sq mi) State map highlighting Mahoning County
Marion County 101 Marion 1. April 1820 Delaware County General Francis Marion (1732–1795) 000000000066217.000000000066.217 000000000001046.00000000001.046 km² (000000000040384.000000000040.384 sq mi) State map highlighting Marion County
Medina County 103 Medina 18. Februar 1812 Portage County Medina, Hauptstadt von Al Madinah in Saudi-Arabien 000000000151095.0000000000151.095 000000000001092.00000000001.092 km² (000000000042155.000000000042.155 sq mi) State map highlighting Medina County
Meigs County 105 Pomeroy 1. April 1819 Gallia und Athens Countys Return Jonathan Meigs Jr. (1764–1825) 000000000023072.000000000023.072 000000000001112.00000000001.112 km² (000000000042942.000000000042.942 sq mi) State map highlighting Meigs County
Mercer County 107 Celina 1. April 1820 Darke County General Hugh Mercer (1726–1777) 000000000040924.000000000040.924 000000000001200.00000000001.200 km² (000000000046327.000000000046.327 sq mi) State map highlighting Mercer County
Miami County 109 Troy 1. März 1807 Montgomery County Miami-Indianer 000000000098868.000000000098.868 000000000001054.00000000001.054 km² (000000000040704.000000000040.704 sq mi) State map highlighting Miami County
Monroe County 111 Woodsfield 29. Januar 1813 Belmont, Washington, und Guernsey Countys James Monroe (1758–1831) 000000000015180.000000000015.180 000000000001180.00000000001.180 km² (000000000045554.000000000045.554 sq mi) State map highlighting Monroe County
Montgomery County 113 Dayton 1. Mai 1803 Hamilton und Wayne Countys General Richard Montgomery (1738–1775) 000000000559062.0000000000559.062 000000000001196.00000000001.196 km² (000000000046168.000000000046.168 sq mi) State map highlighting Montgomery County
Morgan County 115 McConnelsville 29. Dezember 1817 Washington, Guernsey, und Muskingum Countys General Daniel Morgan (c.1735–1802) 000000000014897.000000000014.897 000000000001082.00000000001.082 km² (000000000041766.000000000041.766 sq mi) State map highlighting Morgan County
Morrow County 117 Mount Gilead 1. März 1848 Knox, Marion, Delaware, und Richland Countys Jeremiah Morrow (1771–1852), Gouverneur von Ohio 000000000031628.000000000031.628 000000000001052.00000000001.052 km² (000000000040622.000000000040.622 sq mi) State map highlighting Morrow County
Muskingum County 119 Zanesville 1. März 1803 Washington und Fairfield Countys Ein einheimisches Wort für „Dorf am Fluss“
oder
ein einheimisches Wort für „am Fluss“
000000000084585.000000000084.585 000000000001721.00000000001.721 km² (000000000066463.000000000066.463 sq mi) State map highlighting Muskingum County
Noble County 121 Caldwell 1. April 1851 Monroe, Washington, Morgan, und Guernsey Countys John Noble (1785–1831), ein früher Siedler 000000000014058.000000000014.058 000000000001033.00000000001.033 km² (000000000039900.000000000039.900 sq mi) State map highlighting Noble County
Ottawa County 123 Port Clinton 6. März 1840 Erie, Sandusky, und Lucas Countys Ottawa-Indianer 000000000040985.000000000040.985 000000000000660.0000000000660 km² (000000000025495.000000000025.495 sq mi) State map highlighting Ottawa County
Paulding County 125 Paulding 1. April 1820 Darke County John Paulding (1758–1818) 000000000020293.000000000020.293 000000000001078.00000000001.078 km² (000000000041626.000000000041.626 sq mi) State map highlighting Paulding County
Perry County 127 New Lexington 1. März 1818 Washington, Fairfield, und Muskingum Countys Commodore Oliver Hazard Perry (1785–1819) 000000000034078.000000000034.078 000000000001061.00000000001.061 km² (000000000040978.000000000040.978 sq mi) State map highlighting Perry County
Pickaway County 129 Circleville 1. März 1810 Ross, Fairfield, und Franklin Countys Falschschreibung für den Piqua-Stamm
oder
Eine Ableitung des indianischen Wortes „Piqua“
000000000052727.000000000052.727 000000000001300.00000000001.300 km² (000000000050191.000000000050.191 sq mi) State map highlighting Pickaway County
Pike County 131 Waverly 1. Februar 1815 Ross, Scioto, und Adams Countys General Zebulon Pike (1779–1813), Entdecker von Pikes Peak 000000000027695.000000000027.695 000000000001143.00000000001.143 km² (000000000044149.000000000044.149 sq mi) State map highlighting Pike County
Portage County 133 Ravenna 7. Juni 1807 Trumbull County Abgeleitet vom indianischen portage 000000000152061.0000000000152.061 000000000001275.00000000001.275 km² (000000000049239.000000000049.239 sq mi) State map highlighting Portage County
Preble County 135 Eaton 1. März 1808 Montgomery und Butler Countys Captain Edward Preble (1761–1807) 000000000042337.000000000042.337 000000000001100.00000000001.100 km² (000000000042480.000000000042.480 sq mi) State map highlighting Preble County
Putnam County 137 Ottawa 1. April 1820 Shelby County General Israel Putnam (1718–1790), Offizier im Unabhängigkeitskrieg 000000000034726.000000000034.726 000000000001253.00000000001.253 km² (000000000048387.000000000048.387 sq mi) State map highlighting Putnam County
Richland County 139 Mansfield 1. März 1808 Fairfield County Beschreibung des Bodens in dieser Gegend 000000000128852.0000000000128.852 000000000001287.00000000001.287 km² (000000000049688.000000000049.688 sq mi) State map highlighting Richland County
Ross County 141 Chillicothe 20. August 1798 Adams und Washington Countys James Ross 000000000073345.000000000073.345 000000000001783.00000000001.783 km² (000000000068841.000000000068.841 sq mi) State map highlighting Ross County
Sandusky County 143 Fremont 1. April 1820 Huron County Ein Wort der Irokesen für „kaltes Wasser“ 000000000061792.000000000061.792 000000000001060.00000000001.060 km² (000000000040918.000000000040.918 sq mi) State map highlighting Sandusky County
Scioto County 145 Portsmouth 1. Mai 1803 Adams County Scioto River; Das Wort bedeutet „Hirsch“ in der Sprache der Wyandot 000000000079195.000000000079.195 000000000001586.00000000001.586 km² (000000000061227.000000000061.227 sq mi) State map highlighting Scioto County
Seneca County 147 Tiffin 1. April 1820 Huron County Seneca-Indianer, welche hier lebten 000000000058683.000000000058.683 000000000001426.00000000001.426 km² (000000000055059.000000000055.059 sq mi) State map highlighting Seneca County
Shelby County 149 Sidney 1. April 1819 Miami County General Isaac Shelby (1750–1826) 000000000047910.000000000047.910 000000000001060.00000000001.060 km² (000000000040927.000000000040.927 sq mi) State map highlighting Shelby County
Stark County 151 Canton 13. Februar 1808 Columbiana County General John Stark (1728–1822) 000000000378098.0000000000378.098 000000000001492.00000000001.492 km² (000000000057614.000000000057.614 sq mi) State map highlighting Stark County
Summit County 153 Akron 3. März 1840 Medina, Portage, und Stark Countys Weil hier der Ohio-Kanal seine höchste Stelle erreicht 000000000542899.0000000000542.899 000000000001069.00000000001.069 km² (000000000041272.000000000041.272 sq mi) State map highlighting Summit County
Trumbull County 155 Warren 10. Juli 1800 Jefferson und Wayne Countys Jonathan Trumbull senior (1710–1785), Gouverneur von Connecticut 000000000225116.0000000000225.116 000000000001597.00000000001.597 km² (000000000061648.000000000061.648 sq mi) State map highlighting Trumbull County
Tuscarawas County 157 New Philadelphia 15. März 1808 Muskingum County Tuscarawas River, „Fluss des offenen Mundes“
oder
Tuscarawas-Stamm
000000000090914.000000000090.914 000000000001470.00000000001.470 km² (000000000056758.000000000056.758 sq mi) State map highlighting Tuscarawas County
Union County 159 Marysville 1. April 1820 Delaware, Franklin, Logan, und Madison Countys So genannt, weil es aus vier anderen Countys vereinigt wurde 000000000040909.000000000040.909 000000000001131.00000000001.131 km² (000000000043665.000000000043.665 sq mi) State map highlighting Union County
Van Wert County 161 Van Wert 1. April 1820 Darke County Isaac Van Wart (1760–1828), der den Spion John André während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges festnahm 000000000029659.000000000029.659 000000000001062.00000000001.062 km² (000000000041009.000000000041.009 sq mi) State map highlighting Van Wert County
Vinton County 163 McArthur 23. März 1850 Athens, Gallia, Hocking, Jackson, und Ross Countys Samuel Finley Vinton (1792–1862) 000000000012806.000000000012.806 000000000001072.00000000001.072 km² (000000000041408.000000000041.408 sq mi) State map highlighting Vinton County
Warren County 165 Lebanon 1. Mai 1803 Hamilton County General Joseph Warren (1741–1775), Offizier im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 000000000158383.0000000000158.383 000000000001035.00000000001.035 km² (000000000039963.000000000039.963 sq mi) State map highlighting Warren County
Washington County 167 Marietta 27. Juli 1788 Eines der ursprünglichen Countys George Washington (1732–1799) 000000000063251.000000000063.251 000000000001645.00000000001.645 km² (000000000063515.000000000063.515 sq mi) State map highlighting Washington County
Wayne County 169 Wooster 1. März 1808 Aus noch nicht zugeteiltem Gebiet General Anthony Wayne (1745–1796), Offizier im Unabhängigkeitskrieg 000000000111564.0000000000111.564 000000000001438.00000000001.438 km² (000000000055536.000000000055.536 sq mi) State map highlighting Wayne County
Williams County 171 Bryan 1. April 1820 Darke County David Williams (1754–1831) 000000000039188.000000000039.188 000000000001092.00000000001.092 km² (000000000042174.000000000042.174 sq mi) State map highlighting Williams County
Wood County 173 Bowling Green 1. April 1820 Aus noch nicht zugeteiltem Gebiet Eleazer D. Wood (1783–1814), Gründer von Fort Meigs 000000000121065.0000000000121.065 000000000001599.00000000001.599 km² (000000000061732.000000000061.732 sq mi) State map highlighting Wood County
Wyandot County 175 Upper Sandusky 3. Februar 1845 Marion, Crawford, und Hardin Countys Wyandot-Indianer 000000000022908.000000000022.908 000000000001051.00000000001.051 km² (000000000040561.000000000040.561 sq mi) State map highlighting Wyandot County

mitte

Einzelnachweise

  1. a b EPA County FIPS Code Listing. EPA. Abgerufen am 9. April 2007.
  2. a b c d NACo – Find a County. Archiviert vom Original am 12. Juli 2008. Abgerufen am 22. Juli 2007.
  3. a b Federal Roster: Counties of Ohio, Derivation of Name and Date of Erection. Abgerufen am 22. Juli 2007. (Link nicht mehr abrufbar) [nicht mehr verfügbar]
  4. a b Ohio Genealogy Clickable County Map. Archiviert vom Original am 9. Juni 2008. Abgerufen am 25. Juli 2007. [nicht mehr verfügbar]
  5. The origin of Ohio's country names. rootsweb. Abgerufen am 22. März 2009.
  6. Resolution of 111th Ohio General Assembly designating John Allen as the person for which Allen County was named
  7. Ashtabula, Encyclopædia Britannica, 2007. Abgerufen am 19. November 2007
  8. Cuyahoga River, Encyclopædia Britannica, 2007. Abgerufen am 19. November 2007

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Städte in Ohio — Im amerikanischen Bundesstaat Ohio wird eine Stadt gemäß Abschnitt 703.01(A) des Ohio Revised Code wie folgt definiert: “Municipal corporations, which, at the last federal census, had a population of five thousand or more, or five thousand… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys auf Hawaii — Counties Hawaiis Der US Bundesstaat Hawaii ist in 5 Countys unterteilt: Lage County Fläche Einwohner 1. Juli 2005 Verwaltungs sitz Einwohner 1. April 2000 Bereich …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Lousiana — Parishes in Louisiana Der US Bundesstaat Louisiana in den Vereinigten Staaten ist in 64 Parishes unterteilt. Ihr Status entspricht dem der Countys in den anderen Bundesstaaten. Acadia …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Nevada — Der US Bundesstaat Nevada ist in 17 Countys unterteilt. Die Hauptstadt Carson City ist eine unabhängige Stadt, zählt jedoch nach dem US Census Bureau als County. County Einwohner (1. Juli 2006) Verwaltungssitz Einwohner (1. Juli 2005) Carson City …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Kentucky — Boone Ken ton Camp bell Pend leton Bracken Robertson …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Michigan — Keweenaw Houghton Ontonagon Gogebic Iron Baraga …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Montana — LN FH LK SA MN MS …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Countys in Maryland — Garrett Allegany Washington Frederick Carroll Baltimore …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Counties in North Carolina — Der US Bundesstaat North Carolina ist in 100 Countys unterteilt: Alamance County Alexander County Alleghany County Anson County Ashe County Avery County Beaufort County Bertie County …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Grafschaften in Neumexiko — Der US Bundesstaat New Mexico ist in 33 Countys unterteilt. County Einwohner 1. Juli 2005 Verwaltungssitz Einwohner 1. Juli 2004 Bernalillo 603.562 Albuquerque 484.246 Catron 3.409 Reserve 345 Chav …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”